Última actualización: 16 de Abril de 2015
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 9 años |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A81924045 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ De La Granja 30 - Poligono Industrial De Alcobe (Alcobendas). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Stenzel Stefan Kurt | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
Consejero | Stenzel Stefan Kurt | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
Apoderado | Stenzel Stefan Kurt | 19/09/2013 | 16/04/2015 |
Consejero | Paukner Gerd Ingo | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
Adm. Unico | Paukner Gerd Ingo | 17/12/2014 | 16/04/2015 |
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
SecreNoConsj | Krux Jurgen | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 28/05/2009 | 16/04/2015 |
Apo.Man.Soli | Buchner Holger | 11/12/2014 | 16/04/2015 |
Apoderado | Krux Jurgen | Desconocido | 12/02/2015 |
Presidente | Stenzel Stefan Kurt | 19/09/2013 | 17/12/2014 |
Consejero | Stenzel Stefan Kurt | 19/09/2013 | 17/12/2014 |
Consejero | Paukner Gerd Ingo | 24/01/2011 | 17/12/2014 |
SecreNoConsj | Krux Jurgen | 24/01/2011 | 17/12/2014 |
Consejero | Buchner Holger | 11/12/2014 | 17/12/2014 |
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich | 24/01/2011 | 11/12/2014 |
Apoderado | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich | Desconocido | 11/12/2014 |
Presidente | Hardich Wilhelm Heinrich | 24/01/2011 | 19/09/2013 |
Consejero | Hardich Wilhelm Heinrich | 24/01/2011 | 19/09/2013 |
Apoderado | Hardich Wilhelm Heinrich | Desconocido | 19/09/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Electroop SA.
16
Abr 2015
Con fecha 16/04/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 18462 , F 224, S 8, H M 204403, I/A 24
16
Abr 2015
Con fecha 16/04/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 18462 , F 224, S 8, H M 204403, I/A 24
12
Feb 2015
Con fecha 12/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Krux Jurgen |
Datos registrales: T 18462 , F 224, S 8, H M 204403, I/A 23
17
Dic 2014
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
Datos registrales: T 18462 , F 223, S 8, H M 204403, I/A 22
17
Dic 2014
Con fecha 17/12/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
QUEDAN MODIFICADOS LOS ARTICULOS 10º, 12º, 18º Y 20º DE LOS ESTATUTOS -IMPLICANDO EL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION-..
Datos registrales: T 18462 , F 223, S 8, H M 204403, I/A 22
17
Dic 2014
Con fecha 17/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Paukner Gerd Ingo |
Datos registrales: T 18462 , F 223, S 8, H M 204403, I/A 22
17
Dic 2014
Con fecha 17/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Stenzel Stefan Kurt |
Consejero | Paukner Gerd Ingo |
SecreNoConsj | Krux Jurgen |
Consejero | Buchner Holger |
Datos registrales: T 18462 , F 223, S 8, H M 204403, I/A 22
11
Dic 2014
Con fecha 11/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Stenzel Stefan Kurt |
Consejero | Paukner Gerd Ingo |
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich |
SecreNoConsj | Krux Jurgen |
Datos registrales: T 18462 , F 222, S 8, H M 204403, I/A 21
11
Dic 2014
Con fecha 11/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Buchner Holger |
Datos registrales: T 18462 , F 222, S 8, H M 204403, I/A 21
11
Dic 2014
Con fecha 11/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich |
Datos registrales: T 18462 , F 222, S 8, H M 204403, I/A 21
11
Dic 2014
Con fecha 11/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich |
Datos registrales: T 18462 , F 222, S 8, H M 204403, I/A 21
19
Sep 2013
Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Stenzel Stefan Kurt |
Datos registrales: T 18462 , F 220, S 8, H M 204403, I/A 20
19
Sep 2013
Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Hardich Wilhelm Heinrich |
Datos registrales: T 18462 , F 220, S 8, H M 204403, I/A 20
19
Sep 2013
Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Hardich Wilhelm Heinrich |
Datos registrales: T 18462 , F 220, S 8, H M 204403, I/A 20
27
Jun 2011
Con fecha 27/06/2011, la sociedad cambia su domicilio social a C/ DE LA GRANJA 30 - POLIGONO INDUSTRIAL DE ALCOBE (ALCOBENDAS).
Datos registrales: T 18462 , F 220, S 8, H M 204403, I/A 19
24
Ene 2011
Con fecha 24/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Paukner Gerd Ingo |
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich |
SecreNoConsj | Krux Jurgen |
Consejero | Hardich Wilhelm Heinrich |
Datos registrales: T 18462 , F 219, S 8, H M 204403, I/A 18
24
Ene 2011
Con fecha 24/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sols Rodriguez Candela Alberto |
Datos registrales: T 18462 , F 219, S 8, H M 204403, I/A 18
24
Ene 2011
Con fecha 24/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Ringhand Bernd |
Consejero | Paukner Gerd Ingo |
Consejero | Kunstreich Hans- Jurgen Friedrich |
Secretario | Krux Jurgen |
Consejero | Hardich Wilhelm Heinrich |
Datos registrales: T 18462 , F 219, S 8, H M 204403, I/A 18
28
May 2009
Con fecha 28/05/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 18462 , F 219, S 8, H M 204403, I/A 17
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2015-76-28 | Madrid | 23/04/2015 |
BORME-A-2015-35-28 | Madrid | 20/02/2015 |
BORME-A-2014-246-28 | Madrid | 26/12/2014 |
BORME-A-2014-245-28 | Madrid | 24/12/2014 |
BORME-A-2013-185-28 | Madrid | 27/09/2013 |
BORME-A-2011-128-28 | Madrid | 06/07/2011 |
BORME-A-2011-23-28 | Madrid | 03/02/2011 |
BORME-A-2009-108-28 | Madrid | 10/06/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades