Última actualización: 2 de Octubre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A79264354 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Maria De Molina 41 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Radaelli Alberto | 24/10/2016 | 02/10/2020 |
Consejero | Radaelli Alberto | 23/03/2012 | 02/10/2020 |
VsecrNoConsj | Peña Ramilo Angel | 05/02/2013 | 02/10/2020 |
Apoderado | Peña Ramilo Angel | 03/04/2017 | 02/10/2020 |
Apo.Sol. | Peña Ramilo Angel | 14/07/2016 | 02/10/2020 |
Apo.Man.Soli | Mosquera Calvo Sandra | 26/07/2017 | 02/10/2020 |
Apo.Manc. | Lopez Vega Laura | 03/04/2017 | 02/10/2020 |
Apo.Man.Soli | Lopez Vega Laura | 14/07/2016 | 02/10/2020 |
Apo.Man.Soli | Lopez Vega Laura | 26/07/2017 | 02/10/2020 |
Apo.Man.Soli | Lindariing Erik Andreas | 14/07/2016 | 02/10/2020 |
Presidente | Lindarang Erik Andreas | 18/06/2020 | 02/10/2020 |
Liquidador | Lindarang Erik Andreas | 02/10/2020 | 02/10/2020 |
Consejero | Lindarang Erik Andreas | 20/04/2016 | 02/10/2020 |
Apo.Man.Soli | Lindarang Erik Andreas | 26/07/2017 | 02/10/2020 |
Apoderado | Garcia Calero Ivan | 18/10/2018 | 02/10/2020 |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan | 27/09/2019 | 02/10/2020 |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan | 03/04/2017 | 02/10/2020 |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan | 14/07/2016 | 02/10/2020 |
Apo.Sol. | Diaz Acuña Anna Maria | 14/07/2016 | 02/10/2020 |
Apoderado | Cobos Sastre Patricio Miguel | 18/10/2018 | 02/10/2020 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Ef Travel SA.
02
Oct 2020
Con fecha 02/10/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 35486 , F 49, S 8, H M 1525, I/A 50
02
Oct 2020
Con fecha 02/10/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 35486 , F 49, S 8, H M 1525, I/A 50
02
Oct 2020
Con fecha 02/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Lindarang Erik Andreas |
Datos registrales: T 35486 , F 49, S 8, H M 1525, I/A 50
02
Oct 2020
Con fecha 02/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Radaelli Alberto |
VsecrNoConsj | Peña Ramilo Angel |
Consejero | Norlin Henrik Turesson |
Consejero | Lindarang Erik Andreas |
SecreNoConsj | De Belausteguigoitia Mateache Eneko |
Datos registrales: T 35486 , F 49, S 8, H M 1525, I/A 50
18
Jun 2020
Con fecha 18/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Lindarang Erik Andreas |
Datos registrales: T 35486 , F 48, S 8, H M 1525, I/A 49
27
Sep 2019
Con fecha 27/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Mosquera Calvo Sandra |
Apo.Man.Soli | Moreno Pera Ciriac |
Apo.Man.Soli | Lindarang Erik Andreas |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan |
Datos registrales: T 35486 , F 46, S 8, H M 1525, I/A 48
18
Oct 2018
Con fecha 18/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mosquera Calvo Sandra |
Apoderado | Moreno Pera Ciriac |
Apoderado | Lindarang Erik Andreas |
Apoderado | Garcia Calero Ivan |
Apoderado | Cobos Sastre Patricio Miguel |
Datos registrales: T 35486 , F 44, S 8, H M 1525, I/A 47
16
Oct 2018
Con fecha 16/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Lindarang Erik Andreas |
Datos registrales: T 35486 , F 43, S 8, H M 1525, I/A 46
16
Oct 2018
Con fecha 16/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Norlin Henrik Turesson |
Datos registrales: T 35486 , F 43, S 8, H M 1525, I/A 46
26
Jul 2017
Con fecha 26/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Mosquera Calvo Sandra |
Apo.Man.Soli | Moreno Pera Ciriac |
Apo.Man.Soli | Lopez Vega Laura |
Apo.Man.Soli | Lindarang Erik Andreas |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan |
Datos registrales: T 35486 , F 41, S 8, H M 1525, I/A 45
03
Abr 2017
Con fecha 03/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Peña Ramilo Angel |
Apoderado | Belausteguigoitia Mateache Emilio |
Datos registrales: T 35486 , F 41, S 8, H M 1525, I/A 44
03
Abr 2017
Con fecha 03/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Mosquera Calvo Sandra |
Apo.Man.Soli | Moreno Pera Ciriac |
Apo.Manc. | Lopez Vega Laura |
Apo.Manc. | Lindarang Erik Andreas |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan |
Datos registrales: T 29773 , F 196, S 8, H M 1525, I/A 43
17
Mar 2017
Con fecha 17/03/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Norlin Henrik Turesson |
Datos registrales: T 29773 , F 196, S 8, H M 1525, I/A 42
17
Mar 2017
Con fecha 17/03/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Bengtsson Bjorn Daniel |
Datos registrales: T 29773 , F 196, S 8, H M 1525, I/A 42
24
Oct 2016
Con fecha 24/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Radaelli Alberto |
Consejero | Bengtsson Bjorn Daniel |
Datos registrales: T 29773 , F 195, S 8, H M 1525, I/A 41
14
Jul 2016
Con fecha 14/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Peña Ramilo Angel |
Apo.Man.Soli | Mosquera Calvo Sandra |
Apo.Man.Soli | Lopez Vega Laura |
Apo.Man.Soli | Lindariing Erik Andreas |
Apo.Manc. | Garcia Calero Ivan |
Apo.Sol. | Diaz Acuña Anna Maria |
Apo.Sol. | Belausteguigoitia Mateache Eneko |
Datos registrales: T 29773 , F 192, S 8, H M 1525, I/A 40
14
Jul 2016
Con fecha 14/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mullerat Prat Jaime |
Apoderado | Lopez Vega Laura |
Apoderado | Lindarang Andreas Erik |
Apoderado | Garcia Calero Ivan |
Apoderado | Belgrano Malvina |
Datos registrales: T 29773 , F 192, S 8, H M 1525, I/A 40
20
Abr 2016
Con fecha 20/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Lindarang Erik Andreas |
Datos registrales: T 29773 , F 192, S 8, H M 1525, I/A 39
20
Abr 2016
Con fecha 20/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Boije Af Gennas Susanne Length |
Datos registrales: T 29773 , F 192, S 8, H M 1525, I/A 39
13
Abr 2015
Con fecha 13/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Boije Af Gennas Susanne Length |
Datos registrales: T 29773 , F 192, S 8, H M 1525, I/A 38
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2020-197-28 | Madrid | 09/10/2020 | |
BORME-A-2020-121-28 | Madrid | 25/06/2020 | |
BORME-A-2019-191-28 | Madrid | 04/10/2019 | |
BORME-A-2018-206-28 | Madrid | 25/10/2018 | |
BORME-A-2018-205-28 | Madrid | 24/10/2018 | |
BORME-A-2017-149-28 | Madrid | 07/08/2017 | |
BORME-A-2017-71-28 | Madrid | 12/04/2017 | |
BORME-A-2017-60-28 | Madrid | 28/03/2017 | |
BORME-A-2016-208-28 | Madrid | 31/10/2016 | |
BORME-A-2016-139-28 | Madrid | 21/07/2016 | |
BORME-A-2016-81-28 | Madrid | 28/04/2016 | |
BORME-A-2015-75-28 | Madrid | 22/04/2015 | |
BORME-A-2014-190-28 | Madrid | 06/10/2014 | |
BORME-A-2013-205-28 | Madrid | 25/10/2013 | |
BORME-A-2013-31-28 | Madrid | 14/02/2013 | |
BORME-A-2012-152-28 | Madrid | 09/08/2012 | |
BORME-A-2012-121-28 | Madrid | 27/06/2012 | |
BORME-A-2012-96-28 | Madrid | 23/05/2012 | |
BORME-A-2012-66-28 | Madrid | 04/04/2012 | |
BORME-A-2011-187-28 | Madrid | 30/09/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades