Última actualización: 15 de Enero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08448938 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Ps De Gracia Num.26 P.4 (Barcelona). |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Tejero Vall Alberto | 12/01/2009 | 15/01/2021 |
APODERADO | Maldonado Navarro Damia | 12/01/2009 | 15/01/2021 |
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau | 03/05/2012 | 15/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Audihispana Grant Thornton SLP | 20/05/2009 | 15/01/2021 |
ADM.UNICO | Munera Perez Angel | 30/09/2011 | 03/05/2012 |
APODERADO | Vives Almazan Xavier | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Roca Saiz Gloria | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Masip Ortiz Fernando | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Gonzalez Velasco Pedro | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Garcia Cardo Sergio | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Cordero Kibble Adriana | 18/02/2009 | 30/09/2011 |
ADM.UNICO | Andres Lopez Jesus | Desconocido | 30/09/2011 |
APODERADO | Alvarez Keller Alvaro | Desconocido | 30/09/2011 |
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau | 05/02/2010 | 23/08/2011 |
ADM.CONCURS. | Arqued Alsina Luis Alberto | 05/02/2010 | 23/08/2011 |
AUDIT.CUENT. | Abl Auditores SL | Desconocido | 24/03/2009 |
APODERADO | Tejero Vall Alberto | Desconocido | 12/01/2009 |
APODERADO | Novoa Cunill Anna | Desconocido | 12/01/2009 |
APODERADO | Maldonado Navarro Damia | Desconocido | 12/01/2009 |
APODERADO | Alvarez Keller Alvaro | Desconocido | 12/01/2009 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Edifica Construccion Y Obras Civiles SA.
15
Ene 2021
Con fecha 15/01/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 42953 , F 142, S 8, H B 46254, I/A 93
15
Ene 2021
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 945/2009, AUTO FIRME DE FECHA 30/12/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 42953 , F 142, S 8, H B 46254, I/A 93
15
Ene 2021
Con fecha 15/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau |
Datos registrales: T 42953 , F 142, S 8, H B 46254, I/A 93
17
Mar 2014
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 945/2009, AUTO FIRME DE FECHA 18/02/2014, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.
Datos registrales: T 42953 , F 142, S 8, H B 46254, I/A 92
03
May 2012
Con fecha 03/05/2012 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 91
03
May 2012
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 945/2009, FIRME DE FECHA 23/01/2012, POR EL QUE SE DECLARA INCUMPLIDO EL CONVENIO Y SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 91
03
May 2012
Con fecha 03/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau |
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 91
03
May 2012
Con fecha 03/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Munera Perez Angel |
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 91
06
Oct 2011
Con fecha 06/10/2011, la sociedad cambia su domicilio social a PS DE GRACIA Num.26 P.4 (BARCELONA).
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 90
30
Sep 2011
Con fecha 30/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Vives Almazan Xavier |
APODERADO | Roca Saiz Gloria |
APODERADO | Masip Ortiz Fernando |
APODERADO | Gonzalez Velasco Pedro |
APODERADO | Garcia Cardo Sergio |
APODERADO | Cordero Kibble Adriana |
APODERADO | Alvarez Keller Alvaro |
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 89
30
Sep 2011
Con fecha 30/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Munera Perez Angel |
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 88
30
Sep 2011
Con fecha 30/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Andres Lopez Jesus |
Datos registrales: T 42953 , F 141, S 8, H B 46254, I/A 88
23
Ago 2011
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 945/2009, SENTENCIA FIRME DE FECHA 30/12/2010,POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO RECAIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO.
Datos registrales: T 39956 , F 29, S 8, H B 46254, I/A 87
23
Ago 2011
Con fecha 23/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau |
ADM.CONCURS. | Arqued Alsina Luis Alberto |
Datos registrales: T 39956 , F 29, S 8, H B 46254, I/A 87
05
Feb 2010
JUZGADO MERCANTIL 5 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 945/2009, AUTO FIRME DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 39956 , F 28, S 8, H B 46254, I/A 86
05
Feb 2010
Con fecha 05/02/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Ballve Reyes Pau |
ADM.CONCURS. | Arqued Alsina Luis Alberto |
Datos registrales: T 39956 , F 28, S 8, H B 46254, I/A 86
20
May 2009
Con fecha 20/05/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Audihispana Grant Thornton SLP |
Datos registrales: T 39956 , F 28, S 8, H B 46254, I/A 85
24
Mar 2009
Con fecha 24/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Abl Auditores SL |
Datos registrales: T 39956 , F 28, S 8, H B 46254, I/A 84
26
Feb 2009
Con fecha 26/02/2009, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ADICION ART.-30 BIS.-DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.
Datos registrales: T 39956 , F 27, S 8, H B 46254, I/A 83
18
Feb 2009
Con fecha 18/02/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Cordero Kibble Adriana |
Datos registrales: T 39956 , F 26, S 8, H B 46254, I/A 82
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-14-08 | Barcelona | 22/01/2021 |
BORME-A-2014-58-08 | Barcelona | 25/03/2014 |
BORME-A-2012-91-08 | Barcelona | 16/05/2012 |
BORME-A-2011-198-08 | Barcelona | 18/10/2011 |
BORME-A-2011-194-08 | Barcelona | 11/10/2011 |
BORME-A-2011-167-08 | Barcelona | 01/09/2011 |
BORME-A-2010-32-08 | Barcelona | 17/02/2010 |
BORME-A-2009-101-08 | Barcelona | 01/06/2009 |
BORME-A-2009-64-08 | Barcelona | 03/04/2009 |
BORME-A-2009-48-08 | Barcelona | 11/03/2009 |
BORME-A-2009-41-08 | Barcelona | 02/03/2009 |
BORME-A-2009-14-08 | Barcelona | 22/01/2009 |
BORME-A-2009-6-08 | Barcelona | 12/01/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades