Última actualización: 21 de Diciembre de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 7 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82892993 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Mahonia 2 (Madrid). |
Capital social | 120.000.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Valiente Arche Alejandra-Gabriela | 07/05/2015 | 21/12/2016 |
PreComAudit | Piret Claude | 20/03/2013 | 21/12/2016 |
Consejero | Piret Claude | 25/02/2013 | 21/12/2016 |
Apoderado | Muñoz Porras Teresa | 23/03/2012 | 21/12/2016 |
Apo.Sol. | Muñoz Porras Teresa | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apo.Manc. | Muñoz Porras Teresa | 26/01/2012 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Muñoz Porras Teresa | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Muñoz Porras Teresa | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Auditor | Mazars Auditores SLP | 23/03/2012 | 21/12/2016 |
Auditor | Mazars Auditores SLP | 20/03/2013 | 21/12/2016 |
Apoderado | Martin Borregon Maier Carlos | 07/05/2015 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Martin Borregon Maier Carlos | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apoderado | Lenoir Benoit | 07/05/2015 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Herraez Sepulveda Francisco Javier | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apoderado | Giacobbi Patrick Yves Rene | 13/06/2013 | 21/12/2016 |
Apoderado | Garcia Vazquez Cristina | 07/05/2015 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Garcia Vazquez Cristina | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Garcia Vazquez Cristina | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Enesco Arana Alejandro | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Enesco Arana Alejandro | 28/05/2013 | 21/12/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Dexia Sabadell SA.
21
Dic 2016
Con fecha 21/12/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 31001 , F 48, S 8, H M 276676, I/A 102
21
Dic 2016
CANCELADA la hoja de la sociedad por haberse acreditado la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil de NANTERRE por parte de la sociedad francesa "DEXIA CREDIT LOCAL".
Datos registrales: T 31001 , F 48, S 8, H M 276676, I/A 102
07
Oct 2016
CON FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2.016, SE HA EXPEDIDO CERTIFICACION ACREDITATIVA DE QUE SE HAN REALIZADO CORRECTAMENTE TODOS LOS ACTOS Y TRAMITES PREVIOS A LA FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD "DEXIA SABADEL SA" POR LA FRANCESA "DEXIA CREDIT LOCAL SA".-
Datos registrales: T 31001 , F 47, S 8, H M 276676, I/A 101
10
Jun 2016
Con fecha 10/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 31001 , F 47, S 8, H M 276676, I/A 100
27
May 2016
DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA SOCIEDAD COMO ABSORBIDA DE LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN FRACIA, TOUR DEXIA, LA DEFENSE 2, 1 PASSERELLE DES REFLETS, 92913 LA DEFENSE CEDEX DENOMINADA "DEXIA CREDIT LOCAL SA".
Datos registrales: T 16295 , F 1, S 8, H M 276676, I/A 1/M
28
Abr 2016
Con fecha 28/04/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias DEXIA CREDIT LOCAL SA.
Datos registrales: T 31001 , F 47, S 8, H M 276676, I/A 99
15
Oct 2015
Con fecha 15/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
M.Comit.Aud | Maillot Philippe Pascal |
Datos registrales: T 31001 , F 47, S 8, H M 276676, I/A 98
15
Oct 2015
Con fecha 15/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
M.Comit.Aud | Pouchous Jean Francois |
Datos registrales: T 31001 , F 47, S 8, H M 276676, I/A 98
29
Sep 2015
Con fecha 29/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Maillot Philippe Pascal |
Consejero | Lensel-Martinat Christine Michele Jacqueline |
Consejero | Dupont Nicolas Michel Andre |
Datos registrales: T 31001 , F 46, S 8, H M 276676, I/A 97
29
Sep 2015
Con fecha 29/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Pouchous Jean Francois |
Consejero | Joel Brugieregarde Marc Andre |
Consejero | Bohets Johan Willy Ferdinad |
Datos registrales: T 31001 , F 46, S 8, H M 276676, I/A 97
26
Ago 2015
Con fecha 26/08/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Se añade el Artículo 5.bis a los Estatutos Sociales..
Datos registrales: T 31001 , F 45, S 8, H M 276676, I/A 96
26
Ago 2015
Reducción de capital
Datos registrales: T 31001 , F 45, S 8, H M 276676, I/A 96
26
Ago 2015
Con fecha 26/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 31001 , F 45, S 8, H M 276676, I/A 95
07
May 2015
Con fecha 07/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Valiente Arche Alejandra-Gabriela |
Apoderado | Sabugal Mendez-Trelles Marta |
Apoderado | Muñoz Porras Teresa |
Apoderado | Martin Borregon Maier Carlos |
Apoderado | Marco Ruiz Chatelain Hugo |
Apoderado | Lenoir Benoit |
Apoderado | Herraez Sepulveda Francisco Javier |
Apoderado | Garcia Vazquez Cristina |
Apoderado | Faure Corinne-Clothilde |
Apoderado | Enesco Arana Alejandro |
Apoderado | Corregel Barrio Jose Ramon |
Datos registrales: T 31001 , F 44, S 8, H M 276676, I/A 94
07
May 2015
Con fecha 07/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sabugal Mendez-Trelles Marta |
Datos registrales: T 31001 , F 44, S 8, H M 276676, I/A 94
08
Ago 2014
Con fecha 08/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 31001 , F 44, S 8, H M 276676, I/A 93
13
Ene 2014
Con fecha 13/01/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Conde Fernandez Maria-Amalia |
Datos registrales: T 31001 , F 44, S 8, H M 276676, I/A 92
09
Oct 2013
Con fecha 09/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
M.Comit.Aud | Wahnon Levy Jose |
Datos registrales: T 31001 , F 44, S 8, H M 276676, I/A 91
29
Ago 2013
Con fecha 29/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Bohets Johan Willy Ferdinad |
Datos registrales: T 31001 , F 43, S 8, H M 276676, I/A 90
13
Jun 2013
HA DIMITIDO D. JOSE LUIS CASTILLO VILLA COMO GERENTE DE LA SUCURSAL EN PORTUGAL, Y SE NOMBRA A D. PATRICK YVES RENE GIACOBBI NUEVO GERENTE DE LA MISMA.
Datos registrales: T 31001 , F 42, S 8, H M 276676, I/A 89
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2017-1-28 | Madrid | 02/01/2017 | |
BORME-A-2016-198-28 | Madrid | 17/10/2016 | |
BORME-A-2016-116-28 | Madrid | 20/06/2016 | |
BORME-A-2016-106-28 | Madrid | 06/06/2016 | |
BORME-A-2016-86-28 | Madrid | 06/05/2016 | |
BORME-A-2015-203-28 | Madrid | 23/10/2015 | |
BORME-A-2015-193-28 | Madrid | 08/10/2015 | |
BORME-A-2015-169-28 | Madrid | 04/09/2015 | |
BORME-A-2015-167-28 | Madrid | 02/09/2015 | |
BORME-A-2015-91-28 | Madrid | 18/05/2015 | |
BORME-A-2014-156-28 | Madrid | 19/08/2014 | |
BORME-A-2014-12-28 | Madrid | 20/01/2014 | |
BORME-A-2013-199-28 | Madrid | 17/10/2013 | |
BORME-A-2013-170-28 | Madrid | 06/09/2013 | |
BORME-A-2013-116-28 | Madrid | 21/06/2013 | |
BORME-A-2013-104-28 | Madrid | 05/06/2013 | |
BORME-A-2013-60-28 | Madrid | 01/04/2013 | |
BORME-A-2013-44-28 | Madrid | 05/03/2013 | |
BORME-A-2012-230-28 | Madrid | 30/11/2012 | |
BORME-A-2012-229-28 | Madrid | 29/11/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades