Última actualización: 2 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A81300188 |
Provincia | Pontevedra |
Domicilio | Cmno De Caramuxo 35 (Vigo). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Uchronska Emilia Urszula | 17/01/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Sanz Pinedo Pablo Jesus | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apoderado | Rodriguez Garcia- Lajara Jose Luis | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apo.Man.Soli | Peña Pinto Manuel Jesus | 24/05/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Nielfa Dies Inmaculada | 11/06/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Montes Rodriguez Pablo | 11/06/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Martinez Correcher Enrique | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apoderado | Loureiro Nieto Gustavo | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apoderado | Llorente Rastrilla Carlos | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apo.Man.Soli | Kozierkiewicz Emilia Anna | 17/01/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Iturbe Vila Pedro Enrique | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Apo.Man.Soli | Glowacka Izabela Karina | 14/05/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Fondevila Estevez Ines | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Auditor | Ernst & Young SL | 14/11/2019 | 02/12/2020 |
Auditor | Ernst & Young SL | 15/01/2009 | 02/12/2020 |
Auditor | Ernst & Young SL | 11/01/2018 | 02/12/2020 |
Auditor | Ernst & Young SL | 16/12/2014 | 02/12/2020 |
Apoderado | Chavert Suarez Susana | 11/06/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Bustos Garcia Alfonso | 11/06/2013 | 02/12/2020 |
Apoderado | Alvarez Gonzalez Rafael | 11/06/2013 | 02/12/2020 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Dalphi Metal Seguridad SA.
02
Dic 2020
Con fecha 02/12/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 146, S 8, H PO 56509, I/A 15
02
Dic 2020
Con fecha 02/12/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 146, S 8, H PO 56509, I/A 15
02
Ene 2020
Con fecha 02/01/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias DALPHI METAL ESPAÑA SA.
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 146, S 8, H PO 56509, I/A 14
14
Nov 2019
Con fecha 14/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Trw Automotive Services SL |
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 146, S 8, H PO 56509, I/A 13
07
Nov 2018
Con fecha 07/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 146, S 8, H PO 56509, I/A 12
11
Ene 2018
Con fecha 11/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 145, S 8, H PO 56509, I/A 11
06
Feb 2017
Con fecha 06/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Garcia Falcon Alberto |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 144, S 8, H PO 56509, I/A 10
13
Dic 2016
Con fecha 13/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Galban Rodriguez Lepina Ignacio |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 144, S 8, H PO 56509, I/A 8
28
Nov 2016
Con fecha 28/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 144, S 8, H PO 56509, I/A 7
08
Ene 2016
Con fecha 08/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 143, S 8, H PO 56509, I/A 6
16
Dic 2014
Con fecha 16/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 143, S 8, H PO 56509, I/A 4
28
Jul 2014
Con fecha 28/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 142, S 8, H PO 56509, I/A 3
07
Abr 2014
MODIFICADO el artículo 2 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL.
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 142, S 8, H PO 56509, I/A 2
07
Abr 2014
Con fecha 07/04/2014, la sociedad cambia su domicilio social a CMNO DE CARAMUXO 35 (VIGO).
Datos registrales: T 3950, L 3950, F 100, S 8, H PO 56509, I/A 1
30
Oct 2013
Con fecha 30/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Trw Automotive Services SL |
Datos registrales: T 24897 , F 126, S 8, H M 161626, I/A 66
11
Jun 2013
Con fecha 11/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sieira Gonzalez Tomas Manuel |
Apoderado | Puga Gonzalez Raquel |
Apoderado | Peyre Jean Christophe |
Apoderado | Pardo Manzanares Javier |
Apoderado | Nielfa Dies Inmaculada |
Apoderado | Montes Rodriguez Pablo |
Apoderado | Jonietz Andreas Maria Joachim |
Apoderado | Gonzalo Lopez Alfredo |
Apoderado | Del Rio Garcia Alejandro |
Apoderado | De La Rosa Santana Emilio |
Apoderado | Costas Comesaña Ricardo |
Apoderado | Chavert Suarez Susana |
Apoderado | Bustos Garcia Alfonso |
Apoderado | Alvarez Santana Javier |
Apoderado | Alvarez Gonzalez Rafael |
Datos registrales: T 24897 , F 124, S 8, H M 161626, I/A 65
28
May 2013
Con fecha 28/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Peña Moradiellos Jesus |
Apo.Man.Soli | Galban Rodriguez Lepina Ignacio |
Datos registrales: T 24897 , F 124, S 8, H M 161626, I/A 64
24
May 2013
Con fecha 24/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Peña Pinto Manuel Jesus |
Apo.Man.Soli | Galban Rodriguez Lepina Ignacio |
Datos registrales: T 24897 , F 123, S 8, H M 161626, I/A 63
14
May 2013
Con fecha 14/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Walaszczyk Przemyslaw Jan |
Apo.Man.Soli | Glowacka Izabela Karina |
Datos registrales: T 24897 , F 121, S 8, H M 161626, I/A 62
09
Abr 2013
Con fecha 09/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Paredes Viñas Manuel |
Apo.Manc. | Dominguez Gonzalez Miguel |
Datos registrales: T 24897 , F 120, S 8, H M 161626, I/A 61
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2020-237-36 | Pontevedra | 11/12/2020 | |
BORME-A-2020-7-36 | Pontevedra | 13/01/2020 | |
BORME-A-2019-223-36 | Pontevedra | 20/11/2019 | |
BORME-A-2018-220-36 | Pontevedra | 16/11/2018 | |
BORME-A-2018-14-36 | Pontevedra | 19/01/2018 | |
BORME-A-2017-32-36 | Pontevedra | 15/02/2017 | |
BORME-A-2016-241-36 | Pontevedra | 21/12/2016 | |
BORME-A-2016-232-36 | Pontevedra | 07/12/2016 | |
BORME-A-2016-12-36 | Pontevedra | 20/01/2016 | |
BORME-A-2014-244-36 | Pontevedra | 23/12/2014 | |
BORME-A-2014-147-36 | Pontevedra | 05/08/2014 | |
BORME-A-2014-74-36 | Pontevedra | 16/04/2014 | |
BORME-A-2013-214-28 | Madrid | 08/11/2013 | |
BORME-A-2013-113-28 | Madrid | 18/06/2013 | |
BORME-A-2013-104-28 | Madrid | 05/06/2013 | |
BORME-A-2013-102-28 | Madrid | 03/06/2013 | |
BORME-A-2013-96-28 | Madrid | 24/05/2013 | |
BORME-A-2013-73-28 | Madrid | 18/04/2013 | |
BORME-A-2013-63-28 | Madrid | 04/04/2013 | |
BORME-A-2013-17-28 | Madrid | 25/01/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades