Última actualización: 8 de Marzo de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 1 mes |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B62208186 |
Provincia | Barcelona |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP | 27/01/2012 | 08/03/2018 |
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier | 03/05/2016 | 08/03/2018 |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan | 15/07/2016 | 08/03/2018 |
PRESIDENTE | Gallego Rubio Jorge | 12/08/2015 | 08/03/2018 |
CONSEJERO | Gallego Rubio Jorge | 12/08/2015 | 08/03/2018 |
CONS. DELEG. | Gallego Rubio Jorge | 12/08/2015 | 08/03/2018 |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL | 15/07/2016 | 08/03/2018 |
AUDIT.CUENT. | Bdo Audiberia Auditores SL | 22/01/2010 | 08/03/2018 |
AUDIT.CUENT. | Bdo Audiberia Auditores SL | 18/03/2009 | 08/03/2018 |
CONSEJERO | Lacoma Fernandez Francisco Javier | 24/11/2011 | 15/07/2016 |
SECRETARIO | Griño Tomas Miguel Jose | 26/03/2014 | 15/07/2016 |
CONSEJERO | Griño Tomas Miguel Jose | 26/03/2014 | 15/07/2016 |
PRESIDENTE | Gallego Rubio Jorge | 18/08/2010 | 15/07/2016 |
CONSEJERO | Gallego Rubio Jorge | 18/08/2010 | 15/07/2016 |
CONS. DELEG. | Gallego Rubio Jorge | 18/08/2010 | 15/07/2016 |
APODERADO | Abellan Marichalar Enrique | Desconocido | 08/02/2016 |
REPR.143 RRM | Masia Ayala Maria Teresa | 24/08/2012 | 26/03/2014 |
CONSEJERO | Martinez Ferreira Rafael | 10/12/2010 | 26/03/2014 |
SECR.NO CONS | Jane Bru Jordi | Desconocido | 26/03/2014 |
CONSEJERO | Eficiencia Energetica SA | 25/02/2009 | 26/03/2014 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Coll Cardus Gas SL.
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 45334 , F 102, S 8, H B 215926, I/A 32
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 45334 , F 102, S 8, H B 215926, I/A 32
15
Jul 2016
Con fecha 15/07/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 10,14,15,16,17,19,20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.
Datos registrales: T 45334 , F 102, S 8, H B 215926, I/A 31
15
Jul 2016
Con fecha 15/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 45334 , F 102, S 8, H B 215926, I/A 31
15
Jul 2016
Con fecha 15/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lacoma Fernandez Francisco Javier |
SECRETARIO | Griño Tomas Miguel Jose |
CONSEJERO | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 45334 , F 102, S 8, H B 215926, I/A 31
03
May 2016
Con fecha 03/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
Datos registrales: T 45334 , F 101, S 8, H B 215926, I/A 30
08
Feb 2016
Con fecha 08/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Abellan Marichalar Enrique |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 29
12
Ago 2015
Con fecha 12/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 28
26
Mar 2014
DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO "HERA TRATESA, S.A.".
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 27
26
Mar 2014
Con fecha 26/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Griño Tomas Miguel Jose |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 27
26
Mar 2014
Con fecha 26/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Masia Ayala Maria Teresa |
CONSEJERO | Martinez Ferreira Rafael |
SECR.NO CONS | Jane Bru Jordi |
CONSEJERO | Eficiencia Energetica SA |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 27
24
Ago 2012
Con fecha 24/08/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Masia Ayala Maria Teresa |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 26
24
Ago 2012
Con fecha 24/08/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Marcus Rodriguez Sergio |
Datos registrales: T 36044 , F 204, S 8, H B 215926, I/A 26
27
Ene 2012
Con fecha 27/01/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 25
27
Ene 2012
Con fecha 27/01/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 25
24
Nov 2011
Con fecha 24/11/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Marcus Rodriguez Sergio |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 24
24
Nov 2011
Con fecha 24/11/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Guillen Blecua Cristina |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 24
24
Nov 2011
Con fecha 24/11/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lacoma Fernandez Francisco Javier |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 23
24
Nov 2011
Con fecha 24/11/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Hera Catalunya SL |
REPR.143 RRM | Abellan Marichalar Enrique |
Datos registrales: T 36044 , F 203, S 8, H B 215926, I/A 23
31
Dic 2010
Con fecha 31/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 36044 , F 202, S 8, H B 215926, I/A 22
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-54-08 | Barcelona | 16/03/2018 |
BORME-A-2016-140-08 | Barcelona | 22/07/2016 |
BORME-A-2016-89-08 | Barcelona | 11/05/2016 |
BORME-A-2016-29-08 | Barcelona | 12/02/2016 |
BORME-A-2015-159-08 | Barcelona | 21/08/2015 |
BORME-A-2014-65-08 | Barcelona | 03/04/2014 |
BORME-A-2012-170-08 | Barcelona | 05/09/2012 |
BORME-A-2012-28-08 | Barcelona | 09/02/2012 |
BORME-A-2011-231-08 | Barcelona | 07/12/2011 |
BORME-A-2011-8-08 | Barcelona | 13/01/2011 |
BORME-A-2010-244-08 | Barcelona | 23/12/2010 |
BORME-A-2010-167-08 | Barcelona | 31/08/2010 |
BORME-A-2010-22-08 | Barcelona | 03/02/2010 |
BORME-A-2009-60-08 | Barcelona | 30/03/2009 |
BORME-A-2009-46-08 | Barcelona | 09/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades