Última actualización: 6 de Febrero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
NIF | D32016099 |
Denominación anterior | Pizarras San Gil Sl Scom |
Provincia | Ourense |
Objeto social | La explotación y comercialización de canteras de pizarra y sus productos. |
Capital social | 12.292,84 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 06/02/2024 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 04/04/2023 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 05/04/2022 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/05/2021 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 05/10/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Rummel Frank | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Paul Wranik Martin | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Leon Gonzalez Daniel | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Leon Gonzalez Daniel | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Jager Andreas | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Giron Sanchez Bernardo | 29/01/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Giron Sanchez Bernardo | 29/01/2016 | Actualidad |
Auditor | Ficesa Treuhand SA | 16/05/2014 | Actualidad |
Auditor | Ficesa Treuhand SA | 04/06/2012 | Actualidad |
Apoderado | Reprefiscal SL | 23/11/2010 | Actualidad |
Apo.Manc. | Petermann Gitta | 23/11/2010 | Actualidad |
Apo.Sol. | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 23/11/2010 | Actualidad |
Apo.Manc. | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 23/11/2010 | Actualidad |
Apo.Manc. | Fruhbeck Olmedo Carlos | 23/11/2010 | Actualidad |
Apo.Manc. | Alcalde Stroh- Schein Marco | 23/11/2010 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Schubach Bernd | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Schubach Bernd | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Schubach Bernd | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Sol. | Sanchez Lopez Dionisio | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Sanchez Lopez Dionisio | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Rummel Frank | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Rummel Frank | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Rummel Frank | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Sol. | Leon Gonzalez Daniel | 08/10/2013 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Leon Gonzalez Daniel | 08/10/2013 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Jager Andreas | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Jager Andreas | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Jager Andreas | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Sol. | Giron Sanchez Bernardo | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Sol. | Giron Sanchez Bernardo | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Manc. | Giron Sanchez Bernardo | 23/11/2010 | 29/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Sanchez Lopez Dionisio | Desconocido | 23/11/2010 |
Apo.Manc. | Giron Sanchez Bernardo | Desconocido | 23/11/2010 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Castrelos Elaboracion Sl S. Com .
06
Feb 2024
Con fecha 06/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 845 , F 215, S 8, H OR 1811, I/A 30
04
Abr 2023
Con fecha 04/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 845 , F 215, S 8, H OR 1811, I/A 29
05
Abr 2022
Con fecha 05/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 845 , F 215, S 8, H OR 1811, I/A 28
25
May 2021
Con fecha 25/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 845 , F 214, S 8, H OR 1811, I/A 27
05
Oct 2016
Con fecha 05/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 845 , F 214, S 8, H OR 1811, I/A 26
29
Ene 2016
Con fecha 29/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Rummel Frank |
Datos registrales: T 845 , F 213, S 8, H OR 1811, I/A 25
29
Ene 2016
Con fecha 29/01/2016, la sociedad cambia su actividad a:
La explotación y comercialización de canteras de pizarra y sus productos.
Datos registrales: T 845 , F 213, S 8, H OR 1811, I/A 25
29
Ene 2016
Con fecha 29/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Paul Wranik Martin |
Apo.Manc. | Leon Gonzalez Daniel |
Apo.Manc. | Jager Andreas |
Apo.Sol. | Giron Sanchez Bernardo |
Datos registrales: T 845 , F 213, S 8, H OR 1811, I/A 25
29
Ene 2016
Con fecha 29/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schubach Bernd |
Apo.Manc. | Sanchez Lopez Dionisio |
Apo.Manc. | Rummel Frank |
Apo.Sol. | Leon Gonzalez Daniel |
Apo.Manc. | Jager Andreas |
Apo.Manc. | Giron Sanchez Bernardo |
Datos registrales: T 845 , F 213, S 8, H OR 1811, I/A 25
29
Ago 2014
Se subsana la escritura de segregación parcial de la sociedad Canteras Fernández S.L Extracción S.Com, otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos del Moral Carro, el día 26-05-2014, con el nº 1331 de protocolo, de la que la Compañía Mercantil Castrelos Elaboración SL S. Com es beneficiaria. Y como consecuencia de la segregación, la sociedad beneficiaria aumentó su Capital en un importe nominal correcto de 181.063,54 Euros con una prima de creación de 2.497.102,44 Euros, a una cifra de capital social resultante de 193.175,78 Euros.
Datos registrales: T 845 , F 213, S 8, H OR 1811, I/A 24
18
Jul 2014
Con fecha 18/07/2014, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 180,6 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 1.49% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 12.292,84€.
Datos registrales: T 845 , F 210, S 8, H OR 1811, I/A 23
16
May 2014
Con fecha 16/05/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ficesa Treuhand SA |
Datos registrales: T 845 , F 210, S 8, H OR 1811, I/A 22
17
Mar 2014
Con fecha 17/03/2014, la sociedad cambia su denominación social a CASTRELOS ELABORACION SL S. COM
Datos registrales: T 845 , F 210, S 8, H OR 1811, I/A 21
21
Ene 2014
Sociedades beneficiarias de la escisión: CANTERAS FERNANDEZ, S.L. VIHERMA S. COM.
Datos registrales: T 796 , F 61, S 8, H OR 1811, I/A 20
21
Ene 2014
Reducción de capital
Datos registrales: T 796 , F 61, S 8, H OR 1811, I/A 20
08
Oct 2013
Con fecha 08/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Leon Gonzalez Daniel |
Datos registrales: T 796 , F 60, S 8, H OR 1811, I/A 19
04
Jun 2012
Con fecha 04/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ficesa Treuhand SA |
Datos registrales: T 796 , F 60, S 8, H OR 1811, I/A 18
23
Nov 2010
Con fecha 23/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schubach Bernd |
Apo.Manc. | Sanchez Lopez Dionisio |
Apo.Manc. | Rummel Frank |
Apoderado | Reprefiscal SL |
Apo.Manc. | Petermann Gitta |
Apo.Manc. | Jager Andreas |
Apo.Sol. | Giron Sanchez Bernardo |
Apo.Sol. | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Apo.Manc. | Fruhbeck Olmedo Carlos |
Apo.Manc. | Alcalde Stroh- Schein Marco |
Datos registrales: T 796 , F 59, S 8, H OR 1811, I/A 16
23
Nov 2010
Con fecha 23/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez Lopez Dionisio |
Apo.Manc. | Giron Sanchez Bernardo |
Datos registrales: T 796 , F 59, S 8, H OR 1811, I/A 16
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2024-32-32 | Ourense | 14/02/2024 |
BORME-A-2023-75-32 | Ourense | 20/04/2023 |
BORME-A-2022-73-32 | Ourense | 18/04/2022 |
BORME-A-2021-105-32 | Ourense | 04/06/2021 |
BORME-A-2016-198-32 | Ourense | 17/10/2016 |
BORME-A-2016-43-32 | Ourense | 03/03/2016 |
BORME-A-2016-28-32 | Ourense | 11/02/2016 |
BORME-A-2014-173-32 | Ourense | 11/09/2014 |
BORME-A-2014-144-32 | Ourense | 31/07/2014 |
BORME-A-2014-104-32 | Ourense | 04/06/2014 |
BORME-A-2014-61-32 | Ourense | 28/03/2014 |
BORME-A-2014-21-32 | Ourense | 31/01/2014 |
BORME-A-2013-201-32 | Ourense | 21/10/2013 |
BORME-A-2012-115-32 | Ourense | 19/06/2012 |
BORME-A-2010-247-32 | Ourense | 28/12/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades