Última actualización: 21 de Diciembre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad de Inversión de Capital Variable |
NIF | A82308461 |
Denominación anterior | Gestbos SICAV |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Jose Ortega Y Gasset 7 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ent. Gestora | Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | 25/09/2013 | 21/12/2022 |
Apoderado | Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | 25/09/2013 | 21/12/2022 |
Apoderado | Santander Private Banking Gestion SA | Desconocido | 21/12/2022 |
Consejero | Roldan Lazaro Adolfo | 04/02/2021 | 21/12/2022 |
Consejero | Roldan Lazaro Adolfo | 16/08/2021 | 21/12/2022 |
EntidDeposit | Rbc Investor Services España SA | 09/04/2015 | 21/12/2022 |
Apoderado | Puig Perez Juan | Desconocido | 21/12/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 26/09/2019 | 21/12/2022 |
Consejero | Iborra Cervera Victor | 14/07/2014 | 21/12/2022 |
Ent. Gestora | Gesalcala Sociedad Gestora De Instituciones De Inv | 06/03/2015 | 21/12/2022 |
SecreNoConsj | Garcia Garcia Julia | 04/02/2021 | 21/12/2022 |
Presidente | Faus Santasusana Javier | 14/07/2014 | 21/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 13/07/2016 | 21/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 08/09/2015 | 21/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 29/09/2017 | 21/12/2022 |
Liquidador | Del Pozo Maraver Maria Dolores | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Consejero | Del Pozo Maraver Maria Dolores | 05/02/2018 | 21/12/2022 |
Secretario | Cordoncillo Anton Adalberto | 14/07/2014 | 21/12/2022 |
SecreNoConsj | Cordoncillo Anton Adalberto | 22/04/2010 | 21/12/2022 |
Consejero | Cordoncillo Anton Adalberto | 14/07/2014 | 21/12/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Cartinver Patrimonio SICAV.
21
Dic 2022
Con fecha 21/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 38
21
Dic 2022
Con fecha 21/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 38
21
Dic 2022
Con fecha 21/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Del Pozo Maraver Maria Dolores |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 38
21
Dic 2022
Con fecha 21/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Santander Private Banking Gestion SA |
Apoderado | Reina Amarillas Jose |
Apoderado | Puig Perez Juan |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Apoderado | Faus Santasusana Javier |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 38
21
Dic 2022
Con fecha 21/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Roldan Lazaro Adolfo |
Ent. Gestora | Gesalcala Sociedad Gestora De Instituciones De Inv |
SecreNoConsj | Garcia Garcia Julia |
Consejero | Garcia Fernandez Regatillo Fernando |
Consejero | Del Pozo Maraver Maria Dolores |
EntidDeposit | Banco Inversis SA |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 38
16
Ago 2021
Con fecha 16/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Roldan Lazaro Adolfo |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 37
04
Feb 2021
NOMBRADO POR COOPTACION CONSEJERO DONADOLFO ROLDAN LAZARO.
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 36
04
Feb 2021
Con fecha 04/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Roldan Lazaro Adolfo |
SecreNoConsj | Garcia Garcia Julia |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 36
04
Feb 2021
Con fecha 04/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Ximenez De Embun Monjardin Alvaro |
VsecrNoConsj | Garcia Garcia Julia |
Datos registrales: T 39391 , F 100, S 8, H M 241917, I/A 36
26
Sep 2019
Con fecha 26/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 25474 , F 199, S 8, H M 241917, I/A 35
26
Sep 2019
Con fecha 26/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 25474 , F 199, S 8, H M 241917, I/A 35
28
Jun 2018
REDUCCION DEL CAPITAL POR AMORTIZACION DE ACCIONES PROPIAS EN AUTOCARTERA Y AUMENTO DE CAPITAL POR ELEVACION DE SU VALOR NOMINAL, QUEDANDO MODIFICADAS LAS CIFRAS DEL CAPITAL SOCIAL INICIAL Y ESTATUTARIO MAXIMO QUEDANDO FIJADO EN 2.401.600E Y 24.016.000E, RESPECTIVAMENTE.
Datos registrales: T 25474 , F 199, S 8, H M 241917, I/A 34
05
Feb 2018
Con fecha 05/02/2018, la sociedad cambia su denominación social a CARTINVER PATRIMONIO SICAV SA
Datos registrales: T 25474 , F 198, S 8, H M 241917, I/A 33
05
Feb 2018
Con fecha 05/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Ximenez De Embun Monjardin Alvaro |
Consejero | Garcia Fernandez Regatillo Fernando |
Consejero | Del Pozo Maraver Maria Dolores |
Datos registrales: T 25474 , F 198, S 8, H M 241917, I/A 33
05
Feb 2018
Con fecha 05/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Iborra Cervera Victor |
Presidente | Faus Santasusana Javier |
Secretario | Cordoncillo Anton Adalberto |
Datos registrales: T 25474 , F 198, S 8, H M 241917, I/A 33
29
Sep 2017
Con fecha 29/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 25474 , F 198, S 8, H M 241917, I/A 32
07
Ago 2017
Con fecha 07/08/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificado el artículo 13º de los estatutos sociales.
Datos registrales: T 25474 , F 197, S 8, H M 241917, I/A 31
04
Ago 2017
Con fecha 04/08/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICADO EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ENTIDAD DEPOSITARIA..
Datos registrales: T 25474 , F 197, S 8, H M 241917, I/A 30
04
Ago 2017
Con fecha 04/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
EntidDeposit | Banco Inversis SA |
Datos registrales: T 25474 , F 197, S 8, H M 241917, I/A 30
04
Ago 2017
Con fecha 04/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
EntidDeposit | Bancoval Securities Services SA |
Datos registrales: T 25474 , F 197, S 8, H M 241917, I/A 30
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2022-246-28 | Madrid | 29/12/2022 | |
BORME-A-2021-161-28 | Madrid | 23/08/2021 | |
BORME-A-2021-28-28 | Madrid | 11/02/2021 | |
BORME-A-2019-190-28 | Madrid | 03/10/2019 | |
BORME-A-2018-130-28 | Madrid | 09/07/2018 | |
BORME-A-2018-31-28 | Madrid | 13/02/2018 | |
BORME-A-2017-193-28 | Madrid | 09/10/2017 | |
BORME-A-2017-155-28 | Madrid | 16/08/2017 | |
BORME-A-2017-153-28 | Madrid | 11/08/2017 | |
BORME-A-2016-139-28 | Madrid | 21/07/2016 | |
BORME-A-2015-243-28 | Madrid | 22/12/2015 | |
BORME-A-2015-177-28 | Madrid | 16/09/2015 | |
BORME-A-2015-73-28 | Madrid | 20/04/2015 | |
BORME-A-2015-51-28 | Madrid | 16/03/2015 | |
BORME-A-2014-136-28 | Madrid | 21/07/2014 | |
BORME-A-2013-193-28 | Madrid | 09/10/2013 | |
BORME-A-2013-184-28 | Madrid | 26/09/2013 | |
BORME-A-2012-208-28 | Madrid | 29/10/2012 | |
BORME-A-2010-213-28 | Madrid | 05/11/2010 | |
BORME-A-2010-86-28 | Madrid | 07/05/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades