Última actualización: 11 de Abril de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B63735203 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Rd De Sant Pere Num.39 P.3 Pta.2 (Barcelona). |
Objeto social | Cnae 5520:adquisicion,explotacion y venta de toda clase de bienes inmuebles y derechos reales.explotacion de viviendas y apartamentos turisticos,con finalidad turistica o vacacional,asi apartahoteles,hoteles,hostales,etc. |
Capital social | 27.873,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP | 11/04/2024 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumont Vicente Maria Del Mar | 10/11/2023 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Castellano Saco Belen | 10/11/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Laocoonte Ventures Iberia SL | 09/11/2022 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Casanovas Gimenez Carlos | 09/11/2022 | Actualidad |
CONSEJERO | Casanovas Domenech Jorge | 09/11/2022 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP | 11/06/2021 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP | 02/01/2018 | Actualidad |
CONSEJERO | Xxi Cashi SL | 09/11/2017 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Castello Lopez Yolanda | 09/11/2017 | Actualidad |
CONSEJERO | Castello Lopez Juan | 09/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ros Valls Alexandre | 23/12/2016 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP | 14/07/2015 | Actualidad |
SECRETARIO | Molina Martinez Olga | 30/10/2014 | Actualidad |
PRESIDENTE | Salzberg Barenblit Ezequiel | 23/07/2014 | Actualidad |
CONSEJERO | Salzberg Barenblit Ezequiel | 23/07/2014 | Actualidad |
CONS. DELEG. | Salzberg Barenblit Ezequiel | 23/07/2014 | Actualidad |
CONSEJERO | Molina Martinez Olga | 23/07/2014 | Actualidad |
APODERADO | Molina Martinez Olga | 19/03/2013 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Ros Valls Alexandre | 23/07/2014 | 05/04/2023 |
CONSEJERO | Sanchez Sanchez Carlos | 09/11/2017 | 09/11/2022 |
CONSEJERO | Flaquer Badell Luis Ignacio | 03/05/2017 | 09/11/2022 |
CONSEJERO | Roberto Corradino | 06/04/2016 | 09/11/2017 |
CONSEJERO | Ann M E P Sleebus | 23/07/2014 | 03/04/2017 |
CONSEJERO | Marco Corradino | 23/07/2014 | 06/04/2016 |
SECRETARIO | Ann M E P Sleebus | 23/07/2014 | 30/10/2014 |
ADM.UNICO | Salzberg Barenblit Ezequiel | 11/03/2013 | 23/07/2014 |
ADM.UNICO | Salzberg Barenblit Ezequiel | Desconocido | 11/03/2013 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Aspasion Short Rentals SL.
11
Abr 2024
Con fecha 11/04/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP |
Datos registrales: T 46395 , F 152, S 8, H B 300119, I/A 26
10
Nov 2023
Con fecha 10/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Dumont Vicente Maria Del Mar |
Datos registrales: T 46395 , F 151, S 8, H B 300119, I/A 25
10
Nov 2023
Con fecha 10/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Castellano Saco Belen |
Datos registrales: T 46395 , F 151, S 8, H B 300119, I/A 24
05
Abr 2023
Con fecha 05/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Ros Valls Alexandre |
Datos registrales: T 46395 , F 150, S 8, H B 300119, I/A 23
14
Nov 2022
Con fecha 14/11/2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 3.096,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 12.50% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 27.873,0€.
Datos registrales: T 46395 , F 150, S 8, H B 300119, I/A 22
09
Nov 2022
Con fecha 09/11/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 33.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.
Datos registrales: T 46110 , F 200, S 8, H B 300119, I/A 21
09
Nov 2022
Con fecha 09/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Laocoonte Ventures Iberia SL |
REPR.143 RRM | Casanovas Gimenez Carlos |
CONSEJERO | Casanovas Domenech Jorge |
Datos registrales: T 46110 , F 200, S 8, H B 300119, I/A 21
09
Nov 2022
Con fecha 09/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Sanchez Sanchez Carlos |
CONSEJERO | Flaquer Badell Luis Ignacio |
Datos registrales: T 46110 , F 200, S 8, H B 300119, I/A 21
23
Ago 2021
Sociedades beneficiarias de la escisión: RIGHTPLACE REAL ESTATE S.L.
Datos registrales: T 46110 , F 198, S 8, H B 300119, I/A 20
23
Ago 2021
Con fecha 23/08/2021, la sociedad cambia su actividad a:
CNAE 5520:ADQUISICION,EXPLOTACION Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES.EXPLOTACION DE VIVIENDAS Y APARTAMENTOS TURISTICOS,CON FINALIDAD TURISTICA O VACACIONAL,ASI APARTAHOTELES,HOTELES,HOSTALES,ETC.
Datos registrales: T 46110 , F 198, S 8, H B 300119, I/A 20
23
Ago 2021
Reducción de capital
Datos registrales: T 46110 , F 198, S 8, H B 300119, I/A 20
11
Jun 2021
Con fecha 11/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP |
Datos registrales: T 46110 , F 198, S 8, H B 300119, I/A 19
27
Mar 2018
Con fecha 27/03/2018, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 2.127,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 8.29% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 27.777,0€.
Datos registrales: T 46110 , F 197, S 8, H B 300119, I/A 18
02
Ene 2018
Con fecha 02/01/2018, la sociedad cambia su actividad a:
LA INSTALACION,GESTION Y EXPLOTACION,YA SEA POR CUENTA PROPIA O AJENA,DE APARTAMENTOS Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS,HOTELEROS O EXTRAHOTELEROS,CASAS DE TURISMO RURAL,DE ALQUILER VACACIONAL Y POR TEMPORADA,NEGOCIOS DE TURISMO ...
Datos registrales: T 46110 , F 196, S 8, H B 300119, I/A 17
02
Ene 2018
Con fecha 02/01/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 16.- LUGAR DE CELEBRACION. ARTICULO 20.- REPRESENTACION. ARTICULO 26.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Datos registrales: T 46110 , F 196, S 8, H B 300119, I/A 17
02
Ene 2018
Con fecha 02/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Activa Auditoria & Consultoria SLP |
Datos registrales: T 46110 , F 196, S 8, H B 300119, I/A 17
09
Nov 2017
Con fecha 09/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Xxi Cashi SL |
CONSEJERO | Sanchez Sanchez Carlos |
REPR.143 RRM | Castello Lopez Yolanda |
CONSEJERO | Castello Lopez Juan |
Datos registrales: T 37468 , F 23, S 8, H B 300119, I/A 16
09
Nov 2017
Con fecha 09/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Roberto Corradino |
Datos registrales: T 37468 , F 23, S 8, H B 300119, I/A 16
03
May 2017
Con fecha 03/05/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 15.-CONVOCATORIA.
Datos registrales: T 37468 , F 22, S 8, H B 300119, I/A 15
03
May 2017
Con fecha 03/05/2017, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 5.130,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 25.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 25.650,0€.
Datos registrales: T 37468 , F 22, S 8, H B 300119, I/A 15
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-79-08 | Barcelona | 23/04/2024 | |
BORME-A-2023-219-08 | Barcelona | 17/11/2023 | |
BORME-A-2023-71-08 | Barcelona | 14/04/2023 | |
BORME-A-2022-222-08 | Barcelona | 22/11/2022 | |
BORME-A-2022-219-08 | Barcelona | 17/11/2022 | |
BORME-A-2021-171-08 | Barcelona | 06/09/2021 | |
BORME-A-2021-115-08 | Barcelona | 18/06/2021 | |
BORME-A-2018-66-08 | Barcelona | 05/04/2018 | |
BORME-A-2018-6-08 | Barcelona | 09/01/2018 | |
BORME-A-2017-219-08 | Barcelona | 17/11/2017 | |
BORME-A-2017-88-08 | Barcelona | 11/05/2017 | |
BORME-A-2017-70-08 | Barcelona | 11/04/2017 | |
BORME-A-2017-2-08 | Barcelona | 03/01/2017 | |
BORME-A-2016-71-08 | Barcelona | 14/04/2016 | |
BORME-A-2015-208-08 | Barcelona | 30/10/2015 | |
BORME-A-2015-137-08 | Barcelona | 22/07/2015 | |
BORME-A-2014-215-08 | Barcelona | 11/11/2014 | |
BORME-A-2014-143-08 | Barcelona | 30/07/2014 | |
BORME-A-2014-131-08 | Barcelona | 14/07/2014 | |
BORME-A-2013-61-08 | Barcelona | 02/04/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades