Última actualización: 23 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B62462213 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Remolar Num.2 (Prat De Llobregat (El)). |
Capital social | 5.530.800,0 euros |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECR.NO CONS | Prades Espot Antonio | 17/12/2008 | 23/12/2020 |
APODERADO | Parera Sole Jose Maria | 06/08/2012 | 23/12/2020 |
APODERADO | Parera Sole Jose Maria | 26/02/2013 | 23/12/2020 |
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge | 12/12/2013 | 23/12/2020 |
APODERADO | Martin Moreno Monica | 26/02/2013 | 23/12/2020 |
APODERADO | Martin Moreno Monica | 03/02/2009 | 23/12/2020 |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL | 12/12/2013 | 23/12/2020 |
APODERADO | Foguet Olives Jordi | 26/02/2013 | 23/12/2020 |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente | 12/12/2013 | 23/12/2020 |
APODERADO | Romero Garcia Josep Maria | 26/02/2013 | 01/12/2016 |
APODERADO | Romero Garcia Jose Maria | 03/02/2009 | 01/12/2016 |
APODERADO | Pujol Zamora Jaume | 26/02/2013 | 01/12/2016 |
APODERADO | Ocaña Rodriguez Luis David | 23/10/2012 | 01/12/2016 |
APODERADO | Montero Lastres Maximino | 26/02/2013 | 01/12/2016 |
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro | 06/03/2013 | 01/12/2016 |
APODERADO | Julia Alsina Noemi | 23/10/2012 | 01/12/2016 |
APODERADO | Belles Subirats Xavier | 26/02/2013 | 01/12/2016 |
APODERADO | Belles Subirats Xavier | 03/02/2009 | 01/12/2016 |
APODERADO | Arthur Buck | 23/10/2012 | 01/12/2016 |
APODERADO | Arthur Buck | 26/02/2013 | 01/12/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Artenius Green SL.
23
Dic 2020
Con fecha 23/12/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43373 , F 106, S 8, H B 226781, I/A 42
23
Dic 2020
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/11/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43373 , F 106, S 8, H B 226781, I/A 42
23
Dic 2020
Con fecha 23/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente |
Datos registrales: T 43373 , F 106, S 8, H B 226781, I/A 42
24
Nov 2017
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, AUTO FIRME DE FECHA 05/09/2017, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO.
Datos registrales: T 43373 , F 106, S 8, H B 226781, I/A 41
24
Nov 2017
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, PROVIDENCIA FIRME DE FECHA 28/02/2014, APERTURA DE LA SECCION DE CALIFICACION.
Datos registrales: T 43233 , F 140, S 8, H B 226781, I/A 40
01
Dic 2016
Con fecha 01/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Romero Garcia Josep Maria |
APODERADO | Romero Garcia Jose Maria |
APODERADO | Pujol Zamora Jaume |
APODERADO | Ocaña Rodriguez Luis David |
APODERADO | Montero Lastres Maximino |
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro |
APODERADO | Julia Alsina Noemi |
APODERADO | Crous Millet Antonio |
APODERADO | Belles Subirats Xavier |
APODERADO | Arthur Buck |
Datos registrales: T 43233 , F 140, S 8, H B 226781, I/A 39
09
May 2016
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, PROVIDENCIA FIRME DE FECHA 01/03/2016,CONSTANCIA DEL EJERCICIO INDISTINTO DE LAS FACULTADES DE LAS PERSONAS FISICAS REPRESENTANTES DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL.
Datos registrales: T 43233 , F 138, S 8, H B 226781, I/A 38
12
Ene 2015
Con fecha 12/01/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 43233 , F 139, S 8, H B 226781, I/A 37
12
Ene 2015
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, RESOLUCIONES FIRMES, DE FECHAS 25/11/2013: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 19/12/2013:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43233 , F 139, S 8, H B 226781, I/A 37
12
Ene 2015
Con fecha 12/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | La Seda De Barcelona SA |
REPR.143 RRM | Crous Millet Antonio |
Datos registrales: T 43233 , F 139, S 8, H B 226781, I/A 37
03
Mar 2014
Con fecha 03/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Lopez Hernandez Abelardo |
APODERADO | Foguet Olives Jordi |
Datos registrales: T 43233 , F 139, S 8, H B 226781, I/A 36
12
Dic 2013
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 430/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES.
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 35
12
Dic 2013
Con fecha 12/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 35
02
Ago 2013
Con fecha 02/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Morlanes Galindo Jose Luis |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 34
05
Jul 2013
Con fecha 05/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sandra Maria Soares Santos |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 33
05
Jul 2013
Con fecha 05/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Crous Millet Antonio |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 32
05
Jul 2013
Con fecha 05/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Lopez Hernandez Abelardo |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 32
17
May 2013
Con fecha 17/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Carlos A Moreira Da Silva |
Datos registrales: T 43233 , F 137, S 8, H B 226781, I/A 31
06
Mar 2013
Con fecha 06/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro |
Datos registrales: T 43233 , F 136, S 8, H B 226781, I/A 30
26
Feb 2013
Con fecha 26/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sanz Laguna Carlos Jose |
APODERADO | Gallego Vitoria Jose Miguel |
Datos registrales: T 43233 , F 133, S 8, H B 226781, I/A 28
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2020-250-08 | Barcelona | 31/12/2020 | |
BORME-A-2017-230-08 | Barcelona | 04/12/2017 | |
BORME-A-2016-234-08 | Barcelona | 12/12/2016 | |
BORME-A-2016-93-08 | Barcelona | 18/05/2016 | |
BORME-A-2015-11-08 | Barcelona | 19/01/2015 | |
BORME-A-2014-48-08 | Barcelona | 11/03/2014 | |
BORME-A-2013-242-08 | Barcelona | 19/12/2013 | |
BORME-A-2013-152-08 | Barcelona | 12/08/2013 | |
BORME-A-2013-133-08 | Barcelona | 16/07/2013 | |
BORME-A-2013-100-08 | Barcelona | 30/05/2013 | |
BORME-A-2013-50-08 | Barcelona | 13/03/2013 | |
BORME-A-2013-45-08 | Barcelona | 06/03/2013 | |
BORME-A-2012-214-08 | Barcelona | 07/11/2012 | |
BORME-A-2012-171-08 | Barcelona | 06/09/2012 | |
BORME-A-2012-156-08 | Barcelona | 16/08/2012 | |
BORME-A-2012-121-08 | Barcelona | 27/06/2012 | |
BORME-A-2012-89-08 | Barcelona | 11/05/2012 | |
BORME-A-2011-69-08 | Barcelona | 08/04/2011 | |
BORME-A-2011-54-08 | Barcelona | 18/03/2011 | |
BORME-A-2011-9-08 | Barcelona | 14/01/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades