Última actualización: 22 de Noviembre de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B61979217 |
Provincia | Barcelona |
Objeto social | Ampliar a: la prestacion de servicios de gestion y administracion de siniestros de automoviles,la reparacion de automoviles y la prestacion de servicios de centro de atencion al cliente y atencion telefonica ... |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | Zabaco Chinchilla Fernando | 24/11/2015 | 22/11/2021 |
APODERAD.SOL | Remartinez Porres Emma | 20/10/2017 | 22/11/2021 |
APODERAD.SOL | Remartinez Porres Emma | 14/12/2015 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 11/02/2021 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 04/08/2020 | 22/11/2021 |
CONSEJERO | Olivas Martin Sergio | 03/10/2018 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 24/01/2014 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 18/08/2016 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 12/01/2011 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 16/03/2010 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 05/03/2009 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 19/12/2012 | 22/11/2021 |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 28/02/2012 | 22/11/2021 |
SECR.NO CONS | Jover Calvet Eugenia | 03/12/2020 | 22/11/2021 |
CONSEJERO | Heinz Piskay | 24/11/2015 | 22/11/2021 |
APODERAD.SOL | Girones Miserachs Eva | 23/12/2020 | 22/11/2021 |
APODERAD.SOL | Gea Gelada Ana Maria | 04/10/2016 | 22/11/2021 |
APODERAD.SOL | Cruells Pares Oriol | 04/10/2016 | 22/11/2021 |
APOD.MANCOMU | Cruells Pares Oriol | 01/09/2016 | 22/11/2021 |
V-SEC NO CON | Castro Nabau Miquel | 03/12/2020 | 22/11/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Akzo Nobel Car Refinishes SL.
22
Nov 2021
Con fecha 22/11/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 45513 , F 167, S 8, H B 196046, I/A 50
25
Jun 2021
Con fecha 25/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Gimenez Garcia Gabriel |
Datos registrales: T 45513 , F 165, S 8, H B 196046, I/A 49
25
Jun 2021
Con fecha 25/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Pineda Ferre Jordi |
Datos registrales: T 45513 , F 165, S 8, H B 196046, I/A 49
11
Feb 2021
Con fecha 11/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45513 , F 165, S 8, H B 196046, I/A 48
23
Dic 2020
Con fecha 23/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Girones Miserachs Eva |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 47
23
Dic 2020
Con fecha 23/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Sandra Liliana Gigliotti |
APODERAD.SOL | Milian Alvaro Juan Antonio |
APODERAD.SOL | Cobo Gomez Silvia |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 47
03
Dic 2020
Con fecha 03/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Jover Calvet Eugenia |
V-SEC NO CON | Castro Nabau Miquel |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 46
03
Dic 2020
Con fecha 03/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Rodiguez Cachero Eva Maria |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 46
04
Ago 2020
Con fecha 04/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 45
03
Oct 2018
Con fecha 03/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Olivas Martin Sergio |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 44
03
Oct 2018
Con fecha 03/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Daniela Ana Vlad Smakman |
Datos registrales: T 45513 , F 164, S 8, H B 196046, I/A 44
03
Oct 2018
Con fecha 03/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Pineda Ferre Jordi |
Datos registrales: T 45513 , F 163, S 8, H B 196046, I/A 43
20
Oct 2017
Con fecha 20/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Remartinez Porres Emma |
APODERAD.SOL | Milian Alvaro Juan Antonio |
Datos registrales: T 45513 , F 163, S 8, H B 196046, I/A 42
20
Oct 2017
Con fecha 20/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Jimenez Sanz Miguel Angel |
APODERADO | Gargallo Coscolin Mercedes |
APODERADO | Cobo Gomez Silvia |
Datos registrales: T 45513 , F 163, S 8, H B 196046, I/A 42
21
Feb 2017
Con fecha 21/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45513 , F 163, S 8, H B 196046, I/A 41
16
Ene 2017
Con fecha 16/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Daniela Ana Vlad Smakman |
Datos registrales: T 45513 , F 162, S 8, H B 196046, I/A 40
16
Ene 2017
Con fecha 16/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lucia Donzelli |
Datos registrales: T 45513 , F 162, S 8, H B 196046, I/A 40
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Sandra Liliana Gigliotti |
Datos registrales: T 45513 , F 162, S 8, H B 196046, I/A 39
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Rodiguez Cachero Eva Maria |
Datos registrales: T 45513 , F 162, S 8, H B 196046, I/A 38
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Gargallo Coscolin Mercedes |
Datos registrales: T 45513 , F 162, S 8, H B 196046, I/A 38
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2021-228-08 | Barcelona | 29/11/2021 | |
BORME-A-2021-126-08 | Barcelona | 05/07/2021 | |
BORME-A-2021-34-08 | Barcelona | 19/02/2021 | |
BORME-A-2021-4-08 | Barcelona | 08/01/2021 | |
BORME-A-2020-239-08 | Barcelona | 15/12/2020 | |
BORME-A-2020-155-08 | Barcelona | 12/08/2020 | |
BORME-A-2018-197-08 | Barcelona | 11/10/2018 | |
BORME-A-2017-208-08 | Barcelona | 31/10/2017 | |
BORME-A-2017-42-08 | Barcelona | 01/03/2017 | |
BORME-A-2017-16-08 | Barcelona | 24/01/2017 | |
BORME-A-2016-195-08 | Barcelona | 11/10/2016 | |
BORME-A-2016-172-08 | Barcelona | 08/09/2016 | |
BORME-A-2016-163-08 | Barcelona | 26/08/2016 | |
BORME-A-2015-244-08 | Barcelona | 23/12/2015 | |
BORME-A-2015-229-08 | Barcelona | 01/12/2015 | |
BORME-A-2014-21-08 | Barcelona | 31/01/2014 | |
BORME-A-2014-3-08 | Barcelona | 07/01/2014 | |
BORME-A-2013-239-08 | Barcelona | 16/12/2013 | |
BORME-A-2013-176-08 | Barcelona | 16/09/2013 | |
BORME-A-2012-246-08 | Barcelona | 26/12/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades