Última actualización: 13 de Febrero de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 2 meses |
---|---|
NIF | W0038226G |
Provincia | Madrid |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Sierra Sopranis Francisco Javier | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Sierra Sopranis Francisco Javier | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel | 11/02/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel | 10/08/2010 | 13/02/2018 |
Apo.Manc. | Serrano Villar Miguel-Angel | 30/08/2010 | 13/02/2018 |
Apoderado | Sanmarti Beleta Sylvia | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Ruenes Mariñas Maria Leticia | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Perez Del Real Juan | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Nuño Rio Carlos | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apo.Sol. | Morales Flores Carlota | 23/08/2012 | 13/02/2018 |
Apoderado | Manen De Sola Morales Pedro | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Madurga Garcia Alegre Ignacio | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Lucena Perez Rafael | 11/02/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Lucena Perez Rafael | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Esnarrizaga Zubizarreta Federico | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Diaz Martin Maria Isabel | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Apoderado | Diaz Martin Maria Isabel | 10/08/2010 | 13/02/2018 |
Apo.Manc. | Diaz Martin Maria Isabel | 26/01/2010 | 13/02/2018 |
Apoderado | Ciriza Santero Cesar | 31/08/2011 | 13/02/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Abn Amro Bank N V .
13
Feb 2018
Con fecha 13/02/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 218, S 8, H MA124007, I/A 3
13
Feb 2018
Con fecha 13/02/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 218, S 8, H MA124007, I/A 3
13
Feb 2018
Con fecha 13/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Looyens Kurt Karel Josee |
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 218, S 8, H MA124007, I/A 3
04
Jun 2015
Con fecha 04/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Looyens Kurt Karel Josee |
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 218, S 8, H MA124007, I/A 2
04
Jun 2015
Con fecha 04/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Workel Isabel |
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 218, S 8, H MA124007, I/A 2
15
Jul 2014
Con fecha 15/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Workel Isabel |
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 213, S 8, H MA124007, I/A 1
15
Jul 2014
Comienzo de operaciones: 28.05.14. Objeto social: I) Recepción de depósitos y otros fondos reembolsables; II) Préstamos, incluyendo credito al consumo, credito hipotecario, factoring con o sin recurso y financiación de transacciones comerciales (incluyendo el forfaiting); III) arrendamiento financiero (leasing); IV) Servicios de pago tal y como est. Domicilio: AVDA JOSE BANUS - EDIFICIO MALAGA II 2B, NUEVA AN (MARBELLA). Capital: 0 Ptas.
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 213, S 8, H MA124007, I/A 1
23
Feb 2010
Con fecha 23/02/2010, la sociedad cambia su denominación social a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V SUCURSAL EN ESPAÑA
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 167, S 3, H 43472, I/A 251
23
Feb 2010
LA SOCIEDAD MATRIZ DE ESTA SUCURSAL, "ABN AMRO BANK NV", HACAMBIADO SU DENOMINACION, ADOPTANDO LA DE "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.".
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 167, S 3, H 43472, I/A 251
26
Ene 2010
Con fecha 26/01/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Serrano Villar Miguel-Angel |
Apo.Manc. | Perez Del Real Juan |
Apo.Manc. | Lucena Perez Rafael |
Apo.Manc. | Diaz Martin Maria Isabel |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 165, S 3, H 43472, I/A 250
07
Oct 2009
Con fecha 07/10/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel |
Apoderado | Perez Del Real Juan |
Apoderado | Lucena Perez Rafael |
Apoderado | Diaz Martin Maria Isabel |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 164, S 3, H 43472, I/A 249
03
Jun 2009
Con fecha 03/06/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Zamorano Moro Borja |
Apoderado | Vasallo Tome Jorge Antonio |
Apoderado | Torres Guijarro Blanca |
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel |
Apoderado | Saez De Viteri Fernandez Zuriñe Edurne |
Apoderado | Rodriguez Martin Maria Del Rosario |
Apoderado | Perez Del Real Juan |
Apoderado | Perez Benzecry Ascension |
Apoderado | Goñi Beltran De Garizurieta Jose Javier |
Apoderado | Gabilondo Aristondo Ricardo Felipe |
Apoderado | Bockmann Martin Wolf Dietrich |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 163, S 3, H 43472, I/A 248
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 161, S 3, H 43472, I/A 247
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Perez Yusta Raquel |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 160, S 3, H 43472, I/A 246
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Dominguez Sanchez Manuel Julio |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 158, S 3, H 43472, I/A 245
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Perez Del Real Juan |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 157, S 3, H 43472, I/A 244
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Montoro Lazareno Macarena Sonsoles |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 156, S 3, H 43472, I/A 243
31
Mar 2009
Con fecha 31/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Serrano Villar Miguel-Angel |
Apoderado | Perez Del Real Juan |
Apoderado | Lucena Perez Rafael |
Apoderado | Diaz Martin Maria Isabel |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 154, S 3, H 43472, I/A 242
02
Mar 2009
REVOCADO EL PODER OTORGADO A DON EMILIO PABLO ORDOÑEZ ILLANO, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO EN AMSTERDAM EL 24 DE MAYO DE1.988, QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 44& DE LA HOJA SOCIAL.
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 154, S 3, H 43472, I/A 241
02
Mar 2009
Con fecha 02/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Soto Lombardero Julio Jose |
Apoderado | Navarro Escabias Antonio |
Apoderado | Gonzalez Romero Fernando |
Apoderado | Gomez Valandin Emilio |
Apoderado | Fernandez De Mesa Echeverria Antonio |
Datos registrales: T 10500, L 9030, F 154, S 3, H 43472, I/A 241
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-37-29 | Málaga | 21/02/2018 |
BORME-A-2015-110-29 | Málaga | 15/06/2015 |
BORME-A-2014-139-29 | Málaga | 24/07/2014 |
BORME-A-2010-44-28 | Madrid | 05/03/2010 |
BORME-A-2010-24-28 | Madrid | 05/02/2010 |
BORME-A-2009-199-28 | Madrid | 19/10/2009 |
BORME-A-2009-111-28 | Madrid | 16/06/2009 |
BORME-A-2009-78-28 | Madrid | 27/04/2009 |
BORME-A-2009-77-28 | Madrid | 24/04/2009 |
BORME-A-2009-68-28 | Madrid | 13/04/2009 |
BORME-A-2009-49-28 | Madrid | 12/03/2009 |
BORME-A-2009-23-28 | Madrid | 04/02/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades